Home
Search
Login
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
What's New
Most Wanted
Reports
Dates
Calendar
Cemeteries
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Recordings
Videos
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Bookmarks
Contact Us
Print
Bookmark
Search
•
Advanced Search
•
Search Families
•
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Mary Goodhow
- 1687
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Mary Goodhow
[1]
d. 2 Aug 1687
Samuel Bush
b. 1647 d. 7 May 1733
2
Ebenezer Bush
[1.1]
b. 24 Jul 1687 d. 10 Nov 1757
Miriam
d. 13 Jul 1752
3
Ebenezer Bush
[1.1.1]
b. 1713 d. 15 Feb 1768
Miriam Noble
b. 4 Jan 1710 d. 14 Dec 1752
4
Stephen Bush
[1.1.1.1]
b. Aug 1748 d. 25 Dec 1818
+
Obedience (Pirley) Hall
b. 4 Aug 1755 d. 15 Dec 1827
Caroline Messenger
b. 19 Oct 1754 d. 22 Sep 1788
5
Jr. Stephen Bush
[1.1.1.1.1]
Abigail Nichols
b. 6 Jul 1772 d. 1 May 1831
6
Stephen Nichols Bush
[1.1.1.1.1.1]
b. 29 Mar 1800 d. 1885
Salome N. Morse
b. 1799 d. 1858
7
Frank Bush
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 1829 d. 1897
Harriet Stevens
b. 1829 d. 1911
8
Hattie Bush
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1861
Peter Shutts
9
Gladys Shutts
[1.1.1.1.1.1.1.1.1]
9
Marjorie Shutts
[1.1.1.1.1.1.1.1.2]
9
Irving Shutts
[1.1.1.1.1.1.1.1.3]
9
Glenn Shutts
[1.1.1.1.1.1.1.1.4]
8
Lulu Bush
[1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1863
8
Charles F. Bush
[1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 10 Apr 1865
Emma Frances Hubbard
9
Franklin Bush
[1.1.1.1.1.1.1.3.1]
9
Harriet Stockwell Bush
[1.1.1.1.1.1.1.3.2]
9
Dorothy Bush
[1.1.1.1.1.1.1.3.3]
8
Arthur W. Bush
[1.1.1.1.1.1.1.4]
b. Feb 1870
Mary Hubbard
9
Jr. Arthur W. Bush
[1.1.1.1.1.1.1.4.1]
9
Katherine H. Bush
[1.1.1.1.1.1.1.4.2]
7
Charles Henry Bush
[1.1.1.1.1.1.2]
b. 16 Jul 1831 d. 20 Apr 1895
Mary R. Fuller
b. 23 May 1836 d. 13 Mar 1879
8
Effie L. Bush
[1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 17 May 1865
8
Edward Bush
[1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 5 Aug 1867 d. 17 Sep 1868
8
Irving Fuller Bush
[1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 30 Nov 1870 d. 20 Feb 1930
Eva G. Smalley
d. 16 Mar 1902
9
Ruth Bush
[1.1.1.1.1.1.2.3.1]
Orphie Gant
10
Dorothy Gant
[1.1.1.1.1.1.2.3.1.1]
Robert Hawkins
11
Hawkins
[1.1.1.1.1.1.2.3.1.1.1]
11
Greg Hawkins
[1.1.1.1.1.1.2.3.1.1.2]
11
Meredith Hawkins
[1.1.1.1.1.1.2.3.1.1.3]
11
Jenifer Hawkins
[1.1.1.1.1.1.2.3.1.1.4]
10
Donald W. Gant
[1.1.1.1.1.1.2.3.1.2]
10
Charles Gant
[1.1.1.1.1.1.2.3.1.3]
10
Francis Gant
[1.1.1.1.1.1.2.3.1.4]
9
Everett Bush
[1.1.1.1.1.1.2.3.2]
9
Floyd Bush
[1.1.1.1.1.1.2.3.3]
8
Minerva May Bush
[1.1.1.1.1.1.2.4]
b. Aug 1872
Ida MacMillin
b. 1850 d. 1922
8
Almeda MacMillin Bush
[1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 24 Nov 1883 d. 28 Jan 1979
William Douglas Millar, Sr
b. 11 Oct 1883 d. 4 May 1972
9
Ida Elizabeth Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.1]
b. 2 Sep 1913 d. 20 Oct 1994
William Haynes Kelley, Sr
b. 5 Jun 1913 d. 25 Mar 1980
10
Ann Gaylord Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.5.1.1]
Ralph Wayne Christy
11
Katherine Louise Christy
[1.1.1.1.1.1.2.5.1.1.1]
11
Ralph MacMillin Christy
[1.1.1.1.1.1.2.5.1.1.2]
+
Kimberly Zeender
b. 5 Jan 1978
10
Elizabeth Haynes Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.5.1.2]
b. 14 Apr 1942 d. 25 May 1996
10
William Haynes Kelley, Jr
[1.1.1.1.1.1.2.5.1.3]
Martha Elizabeth Stephenson
b. 11 Jan 1952 d. 16 Apr 1982
11
Douglas Haynes Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.5.1.3.1]
Cornelia McCall Ellefson
12
Jessie Crosswell Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.5.1.3.1.1]
12
Martha McCall Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.5.1.3.1.2]
Melanie Ford
11
William Ford Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.5.1.3.2]
Kathryn Osteen
12
Celia Rose Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.5.1.3.2.1]
12
Edith Ryn Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.5.1.3.2.2]
9
William Douglas Millar, Jr
[1.1.1.1.1.1.2.5.2]
b. 7 Dec 1914 d. 11 Jan 1996
Lillian Naismith
b. 30 Jan 1913 d. 23 Apr 1995
10
Mary Anne Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.2.1]
10
William Douglas Millar, III
[1.1.1.1.1.1.2.5.2.2]
Sarah Denise Cozad
11
Allison Sarah Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.2.2.1]
11
William Douglas Millar, IV
[1.1.1.1.1.1.2.5.2.2.2]
9
Martha Louise Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.3]
+
Augustus Gaines Williams, Jr.
b. 15 Mar 1913 d. 22 Jun 2003
9
Edward Adams Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4]
Dorothy Lee Chamberlin
10
Randall Hackett Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.1]
Carol Marie Riedel
11
Eric Randall Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.1.1]
Lise
12
Amelie Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.1.1.1]
11
Jeffrey Lee Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.1.2]
Susannah
12
Hannah Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.1.2.1]
12
Jack Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.1.2.2]
11
Sean Douglas Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.1.3]
10
Rebecca Gaines Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2]
Roger Allen Jones
11
Christopher Edward Jones
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2.1]
11
Brian Joseph Jones
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2.2]
b. 24 Sep 1977 d. 24 Sep 1977
11
Carin Rebecca Jones
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2.3]
b. 22 May 1978 d. 22 May 1978
11
Katherine Marie Jones
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2.4]
11
Gillian Leigh Jones
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2.5]
11
Andrew Allen Jones
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2.6]
11
Erin Christine Jones
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2.7]
10
Robert Fredrick Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.3]
+
Nina
10
Richard Edward Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.4]
Elaine
11
Andrew Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.4.1]
11
Nicholas Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.4.2]
11
Caite Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.4.3]
10
Thomas Lee Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.5]
10
Walter MacMillin Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.6]
Lynn Ann Plotkin
11
Alison Dasha Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.6.1]
10
Dorothy Lee Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.7]
Rod Buss
11
Scott Buss
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.7.1]
11
Alex Buss
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.7.2]
11
Paul Augustus Buss
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.7.3]
10
Martha Louise Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.8]
+
Michael Thomas Falduto
10
Ronald Douglas Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.9]
+
Kristen_(?)
10
Christine Ann Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.10]
9
Donald Bush Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.5]
Eileen Louise Benson
b. 9 Jul 1925
10
Andrew Douglas Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.5.1]
b. 13 Feb 1949 d. 25 Feb 1958
10
Melinda Laurie Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.5.2]
Dudley Schadeberg
11
Lorna Haviland Schadeberg
[1.1.1.1.1.1.2.5.5.2.1]
+
David Horres
10
Donald MacMillan Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.5.3]
10
Lorna Gale Millar
[1.1.1.1.1.1.2.5.5.4]
Robert Brunhofer
11
Andrew Brunhofer
[1.1.1.1.1.1.2.5.5.4.1]
11
Matthew Brunhofer
[1.1.1.1.1.1.2.5.5.4.2]
7
John Edward Bush
[1.1.1.1.1.1.3]
b. 5 Nov 1835 d. 2 Jan 1917
Marian Cornelia Woodruff
d. 1876
8
George Woodruff Bush
[1.1.1.1.1.1.3.1]
8
Jennie C. Bush
[1.1.1.1.1.1.3.2]
b. Sep 1866
Isabella G. Kenyon
b. Jul 1846
8
Laura Belle Bush
[1.1.1.1.1.1.3.3]
8
Bessie May Bush
[1.1.1.1.1.1.3.4]
8
John Kenyon Bush
[1.1.1.1.1.1.3.5]
b. Apr 1878
8
Edward Morse Bush
[1.1.1.1.1.1.3.6]
b. Jul 1883
8
Ralph H. Bush
[1.1.1.1.1.1.3.7]
b. Dec 1887
7
H. Frederick Bush
[1.1.1.1.1.1.4]
b. 1839
7
Jennie Bush
[1.1.1.1.1.1.5]
b. 1841
+
Church
Jeannette Coats
b. 20 May 1835 d. 5 Mar 1901
7
Katherine Bush
[1.1.1.1.1.1.6]
b. 1861
Oscar Carey
8
Evelyn Carey
[1.1.1.1.1.1.6.1]
8
Belle Carey
[1.1.1.1.1.1.6.2]
8
Gene Carey
[1.1.1.1.1.1.6.3]
8
Irene Carey
[1.1.1.1.1.1.6.4]
8
Joe Carey
[1.1.1.1.1.1.6.5]
+
Polly Squier
b. 15 Feb 1788 d. 17 Jan 1833
+
Susannah Remington Kingsley
+
Thankful (Hitchcock) Phelps
b. 18 Oct 1689 d. 5 Dec 1773
This site powered by
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding
, Copyright © 2001-2006, created by Darrin Lythgoe, Sandy, Utah. All rights reserved.